-
BRIO RETIREMENT LIVING (CHAPELTON) LIMITED - 1 Hay Avenue, Edinburgh, EH16 4RW, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC557400
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Hay Avenue
- Edinburgh
- EH16 4RW
- Scotland 1 Hay Avenue, Edinburgh, EH16 4RW, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- WINSTANLEY, Andrew
- FULLER, Timothy Edward
- Prokuristen
- ALSOP, Joanna Kate
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.02.2017
- Alter der Firma 2017-02-13 7 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- Places For People Retirement Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- LIBERTY RETIREMENT LIVING (CHAPELTON) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-27
- Letzte Einreichung: 2023-02-13
-
BRIO RETIREMENT LIVING (CHAPELTON) LIMITED Firmenbeschreibung
- BRIO RETIREMENT LIVING (CHAPELTON) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC557400. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.02.2017 registriert. BRIO RETIREMENT LIVING (CHAPELTON) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LIBERTY RETIREMENT LIVING (CHAPELTON) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 Hay Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern BRIO RETIREMENT LIVING (CHAPELTON) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Brio Retirement Living (Chapelton) Limited - 1 Hay Avenue, Edinburgh, EH16 4RW, Scotland, Grossbritannien
- 2017-02-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRIO RETIREMENT LIVING (CHAPELTON) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-01-27) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-13) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-04-04) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-07-03) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-07-03) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-12-29) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-23) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-11-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-18) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-18) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-12-20) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-12-01) - PSC05
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2021-12-20) - CH03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-12-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-07-24) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control-without-name-date (2020-07-23) - PSC05
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-21) - MR04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-04-06) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-06) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-20) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-11) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-11) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-08-11) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-15) - CS01
-
memorandum-articles (2019-01-21) - MA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-11-07) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-11) - TM01
-
resolution (2018-11-21) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-08) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-29) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-10) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-10) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-07-04) - PSC05
-
resolution (2018-04-11) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
incorporation-company (2017-02-13) - NEWINC
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-31) - PSC02
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-06-30) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-31) - PSC07