-
TOGETHER ENERGY LIMITED - Level 2 176 St Vincent Street, The Beacon, Glasgow, G2 5SG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC533489
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Level 2 176 St Vincent Street
- The Beacon
- Glasgow
- G2 5SG Level 2 176 St Vincent Street, The Beacon, Glasgow, G2 5SG UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.04.2016
- Alter der Firma 2016-04-25 8 Jahre
- SIC/NACE
- 47990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Scott Richards
- -
- Warrington Borough Council
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- In Administration
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-07-31
- Letzte Einreichung: 2020-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-08
- Letzte Einreichung: 2021-04-24
-
TOGETHER ENERGY LIMITED Firmenbeschreibung
- TOGETHER ENERGY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC533489. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.04.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47990" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Level 2 176 St Vincent Street erreicht werden.
Jetzt sichern TOGETHER ENERGY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Together Energy Limited - Level 2 176 St Vincent Street, The Beacon, Glasgow, G2 5SG, Grossbritannien
- 2016-04-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TOGETHER ENERGY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-in-administration-extension-of-period-scotland (2024-01-11) - AM19(Scot)
-
liquidation-in-administration-progress-report-scotland (2024-02-09) - AM10(Scot)
keyboard_arrow_right 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-06-14) - TM01
-
liquidation-in-administration-progress-report-scotland (2023-03-06) - AM10(Scot)
-
liquidation-in-administration-extension-of-period-scotland (2023-01-25) - AM19(Scot)
-
liquidation-in-administration-progress-report-scotland (2023-09-01) - AM10(Scot)
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-in-administration-progress-report-scotland (2022-08-31) - AM10(Scot)
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-05-31) - TM01
-
liquidation-in-administration-notice-administrators-proposals-scotland (2022-03-30) - AM03(Scot)
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator-scotland (2022-02-10) - AM01(Scot)
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-02-10) - AD01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-decision-scotland (2022-04-21) - AM07(Scot)
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-01) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-08-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-30) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-11-04) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-11-03) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-03) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-03) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-27) - PSC02
-
memorandum-articles (2019-10-21) - MA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-27) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-06-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-22) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-05) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-05) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-10) - AP01
-
resolution (2019-10-21) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-10-21) - SH10
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-21) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-21) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-31) - PSC03
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-11-08) - AA01
-
capital-allotment-shares (2019-10-21) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-01-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-11) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-09) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-31) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-31) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-21) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-01-16) - SH01
-
resolution (2018-01-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-05-10) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-09-22) - SH01
-
resolution (2016-09-22) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2016-04-25) - NEWINC