-
SAFE AS HOUSES LIMITED - Units 16-, 20 Enterprise House, Springkerse Business Park, Stirling, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC514186
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Units 16-
- 20 Enterprise House
- Springkerse Business Park
- Stirling
- FK7 7UF
- Scotland Units 16-, 20 Enterprise House, Springkerse Business Park, Stirling, FK7 7UF, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- CUNNINGHAM, Scott Campbell
- FAIRWEATHER, James Beattie
- RITCHIE, David Innes
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.08.2015
- Alter der Firma 2015-08-27 8 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr David Ashton
- Amity Partnership Holdings Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-02
- Letzte Einreichung: 2023-12-19
-
SAFE AS HOUSES LIMITED Firmenbeschreibung
- SAFE AS HOUSES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC514186. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.08.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Units 16- erreicht werden.
Jetzt sichern SAFE AS HOUSES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Safe As Houses Limited - Units 16-, 20 Enterprise House, Springkerse Business Park, Stirling, Grossbritannien
- 2015-08-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SAFE AS HOUSES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-notice-compulsory (2024-02-27) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-19) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-08-02) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-21) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-30) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-02-14) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-24) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-28) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-12-19) - PSC09
-
capital-allotment-shares (2019-11-22) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-19) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-07) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-19) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-12) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-09-20) - PSC08
-
capital-allotment-shares (2018-09-12) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-28) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-19) - PSC02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-13) - PSC02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-13) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-06) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-06) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-06) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-04) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-16) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-16) - CH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-05) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-26) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-05) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-06) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-21) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-10-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-08-27) - NEWINC