-
PARK DEVELOPMENTS (SCOTLAND) LIMITED - Radleigh House 1 Golf Road, Clarkston, Glasgow, G76 7HU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC513288
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Radleigh House 1 Golf Road
- Clarkston
- Glasgow
- G76 7HU
- United Kingdom Radleigh House 1 Golf Road, Clarkston, Glasgow, G76 7HU, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- MITCHELL, Bradley
- RUFFLER, William Robert
- Prokuristen
- GOW, Iain
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.08.2015
- Alter der Firma 2015-08-17 8 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Bradley Mitchell
- -
- Mr Bradley Mitchell
- Mr William Robert Ruffler
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-05-31
- Letzte Einreichung: 2023-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-19
- Letzte Einreichung: 2023-08-05
-
PARK DEVELOPMENTS (SCOTLAND) LIMITED Firmenbeschreibung
- PARK DEVELOPMENTS (SCOTLAND) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC513288. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.08.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Radleigh House 1 Golf Road erreicht werden.
Jetzt sichern PARK DEVELOPMENTS (SCOTLAND) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Park Developments (Scotland) Limited - Radleigh House 1 Golf Road, Clarkston, Glasgow, G76 7HU, Grossbritannien
- 2015-08-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PARK DEVELOPMENTS (SCOTLAND) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-30) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-12-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-21) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-09-21) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-09-21) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-16) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-04-17) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-09-18) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-12-14) - AP03
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-09-29) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-30) - AA
-
legacy (2019-06-19) - RP04CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-04) - AAMD
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-16) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-02-08) - MR01
-
capital-allotment-shares (2017-02-09) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-12-21) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-05) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-08-17) - NEWINC