-
RIGQUIP HOLDINGS LIMITED - Johnstone House, 52-54 Rose Street, Aberdeen, AB10 1HA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC500716
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Johnstone House
- 52-54 Rose Street
- Aberdeen
- AB10 1HA
- United Kingdom Johnstone House, 52-54 Rose Street, Aberdeen, AB10 1HA, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- FRASER, Craig Kelly
- FRASER, Daniel
- FRASER, Lesley
- FRASER, Matthew Spence
- Prokuristen
- LC SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-17 9 Jahre
- SIC/NACE
- 46140
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- LEDGE 1116 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-17
-
RIGQUIP HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- RIGQUIP HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC500716. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.03.2015 registriert. RIGQUIP HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LEDGE 1116 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46140" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Johnstone House erreicht werden.
Jetzt sichern RIGQUIP HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rigquip Holdings Limited - Johnstone House, 52-54 Rose Street, Aberdeen, AB10 1HA, Grossbritannien
- 2015-03-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RIGQUIP HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-17) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-11) - PSC07
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-02-11) - SH08
-
resolution (2020-02-11) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-02-19) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-02-11) - PSC08
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-07) - AA
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2020-02-24) - 466(Scot)
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2020-02-27) - 466(Scot)
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-03-08) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-18) - CS01
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2019-03-08) - SH02
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-14) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-26) - CS01
-
resolution (2018-09-10) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2018-09-10) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2017-10-13) - SH02
-
resolution (2017-10-13) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-07) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-16) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-09-14) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-04) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-09-14) - SH08
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-17) - AR01
-
capital-allotment-shares (2016-09-12) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-31) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-02) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-04-13) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-04-13) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2015-04-23) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-29) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-01) - MR01
-
resolution (2015-05-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-05-01) - SH01
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2015-05-26) - 466(Scot)
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2015-05-28) - 466(Scot)
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-16) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-15) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-11-10) - MR04
-
incorporation-company (2015-03-17) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-31) - TM01