-
SUN HOMES LIMITED - 1 Macdowall Street, Suite 3.1, Paisley, PA3 2NB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC490432
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Macdowall Street
- Suite 3.1
- Paisley
- PA3 2NB
- Scotland 1 Macdowall Street, Suite 3.1, Paisley, PA3 2NB, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- SINGH, Baljit
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.11.2014
- Alter der Firma 2014-11-04 9 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Mr Baljit Singh
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-24
- Letzte Einreichung: 2023-03-10
-
SUN HOMES LIMITED Firmenbeschreibung
- SUN HOMES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC490432. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.11.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 Macdowall Street erreicht werden.
Jetzt sichern SUN HOMES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sun Homes Limited - 1 Macdowall Street, Suite 3.1, Paisley, PA3 2NB, Grossbritannien
- 2014-11-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SUN HOMES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-dissolved-voluntary (2024-02-20) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-23) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-11-01) - MR04
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-11-27) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2023-12-05) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-02-16) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-03-10) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-03-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-10) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-05-25) - MR04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-11-10) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-02-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-02) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-30) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-08-02) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-08-02) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-08-02) - PSC07
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-26) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-20) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-09) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-20) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-20) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-20) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-25) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-09-18) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-03) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-14) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-10-01) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-08) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-05) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-21) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-11-04) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-24) - AP01