-
MAC & WILD RESTAURANTS LIMITED - Suite 9, River Court, 5 West Victoria Dock Road, Dundee, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC484687
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 9
- River Court
- 5 West Victoria Dock Road
- Dundee
- DD1 3JT Suite 9, River Court, 5 West Victoria Dock Road, Dundee, DD1 3JT UK
Management
- Geschäftsführung
- MACKINNON, Calum Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.08.2014
- Alter der Firma 2014-08-19 9 Jahre
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mac & Wild Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- MAC & WILD LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-02
- Letzte Einreichung: 2020-08-19
-
MAC & WILD RESTAURANTS LIMITED Firmenbeschreibung
- MAC & WILD RESTAURANTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC484687. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.08.2014 registriert. MAC & WILD RESTAURANTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MAC & WILD LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Suite 9 erreicht werden.
Jetzt sichern MAC & WILD RESTAURANTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mac & Wild Restaurants Limited - Suite 9, River Court, 5 West Victoria Dock Road, Dundee, Grossbritannien
- 2014-08-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MAC & WILD RESTAURANTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-24) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-12-03) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-02) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2019-11-26) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-29) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-04) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-11-07) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-27) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2018-11-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-10-31) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-22) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-22) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-22) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-22) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-05) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-01) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2016-02-02) - CERTNM
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-03-31) - SH02
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-04-18) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-18) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-05-18) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-18) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-08-17) - SH01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-09-07) - SH10
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-07) - AP01
-
resolution (2016-09-12) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-09-14) - SH02
-
capital-allotment-shares (2016-09-14) - SH01
-
resolution (2016-09-14) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2016-09-15) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2016-09-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-20) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-09-07) - SH08
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-11) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-08-19) - NEWINC