-
LITTLETON AD LIMITED - 64a Cumberland Street, Edinburgh, EH3 6RE, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC481707
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 64a Cumberland Street
- Edinburgh
- EH3 6RE
- Scotland 64a Cumberland Street, Edinburgh, EH3 6RE, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- DODDS, Robert Andrew
- HORNHUBER, Martin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.07.2014
- Alter der Firma 2014-07-08 9 Jahre
- SIC/NACE
- 38210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Werner Leiter
- Jorg Johannes Jakobljevich
- Mathilde Umdasch
- -
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-22
- Letzte Einreichung: 2020-07-08
-
LITTLETON AD LIMITED Firmenbeschreibung
- LITTLETON AD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC481707. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.07.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "38210" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 64A Cumberland Street erreicht werden.
Jetzt sichern LITTLETON AD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Littleton Ad Limited - 64a Cumberland Street, Edinburgh, EH3 6RE, Scotland, Grossbritannien
- 2014-07-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LITTLETON AD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-11-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-25) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-07) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-02-07) - PSC09
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-21) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-22) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-07-22) - PSC08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-22) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-20) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-07) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-26) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-15) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-10) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-08) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-07) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-02) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-20) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-20) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-11) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-05-22) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-03-23) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-11) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-04-04) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-25) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-26) - TM01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-08-26) - SH08
-
capital-allotment-shares (2015-08-26) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-26) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-02) - AR01
-
resolution (2015-08-26) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-07-08) - NEWINC