-
DAXPORT SCOTLAND LTD - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC481607
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 272 Bath Street
- Glasgow
- G2 4JR
- Scotland 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- COCHRANE, Alison Mary
- COCHRANE, James Alistair Kirkland
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.07.2014
- Alter der Firma 2014-07-07 9 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Daxport Uk Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Ehemalige Namen
- APSIS SOLUTIONS (DEVELOPMENTS) LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-02-04
- Letzte Einreichung: 2022-01-21
-
DAXPORT SCOTLAND LTD Firmenbeschreibung
- DAXPORT SCOTLAND LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC481607. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.07.2014 registriert. DAXPORT SCOTLAND LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen APSIS SOLUTIONS (DEVELOPMENTS) LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 272 Bath Street erreicht werden.
Jetzt sichern DAXPORT SCOTLAND LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Daxport Scotland Ltd - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland, Grossbritannien
- 2014-07-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DAXPORT SCOTLAND LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-05-11) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-07-01) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-01-12) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-02-06) - TM02
-
gazette-notice-compulsory (2023-04-11) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-24) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-03-16) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-23) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-02) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-02) - PSC07
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-29) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-26) - PSC02
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-20) - AD01
-
resolution (2017-03-29) - RESOLUTIONS
-
resolution (2017-03-20) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-02) - CS01
-
resolution (2017-04-21) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-05-26) - AP03
-
resolution (2017-04-10) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-20) - TM01
-
resolution (2017-06-21) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-06-21) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2017-06-21) - SH10
-
capital-allotment-shares (2017-06-21) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-17) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-08) - TM01
-
capital-allotment-shares (2015-02-03) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-02-03) - SH08
-
resolution (2015-02-03) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-29) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-10-14) - AA01
-
incorporation-company (2014-07-07) - NEWINC