-
CHURCHILL HOMES (CULTER HOUSE) LIMITED - Brodies House, 31-33 Union Grove, Aberdeen, AB10 6SD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC480767
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Brodies House
- 31-33 Union Grove
- Aberdeen
- AB10 6SD
- United Kingdom Brodies House, 31-33 Union Grove, Aberdeen, AB10 6SD, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- PIRIE, Gordon Duncan
- PIRIE, Rhona Ann
- Prokuristen
- PIRIE, Rhona Ann
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-25 9 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Gordon Duncan Pirie
- Rhona Ann Pirie
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- FIELDTIDE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-31
- Letzte Einreichung: 2023-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-09
- Letzte Einreichung: 2023-06-25
-
CHURCHILL HOMES (CULTER HOUSE) LIMITED Firmenbeschreibung
- CHURCHILL HOMES (CULTER HOUSE) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC480767. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.06.2014 registriert. CHURCHILL HOMES (CULTER HOUSE) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FIELDTIDE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Brodies House erreicht werden.
Jetzt sichern CHURCHILL HOMES (CULTER HOUSE) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Churchill Homes (Culter House) Limited - Brodies House, 31-33 Union Grove, Aberdeen, AB10 6SD, Grossbritannien
- 2014-06-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHURCHILL HOMES (CULTER HOUSE) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-01-15) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-27) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-11-10) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-04-12) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-04) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-04-21) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2022-07-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-09) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-12-06) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-13) - MR01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-02) - AA
-
resolution (2019-01-16) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-09) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-30) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-22) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-14) - AA
-
memorandum-articles (2016-03-30) - MA
-
resolution (2016-03-30) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-11) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-03-30) - SH08
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-06-02) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-06-02) - AP03
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-07-21) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-06-25) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-19) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-01) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-01) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-09-01) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-01) - AP01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2014-09-01) - AP04
-
resolution (2014-09-04) - RESOLUTIONS
-
resolution (2014-10-15) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-10-15) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-06) - MR01
-
mortgage-alter-floating-charge (2014-11-07) - 466(Scot)
-
certificate-change-of-name-company (2014-09-04) - CERTNM