-
DUAL HOMES AND LAND LIMITED - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC465979
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 272 Bath Street
- Glasgow
- G2 4JR 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR UK
Management
- Geschäftsführung
- HELLE, Tore Johannes
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.12.2013
- Alter der Firma 2013-12-17 10 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Johannes Tore Helle
- -
- Jan Sheila Helle
- Mr Tore Johannes Helle
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- FSTEER HOLDINGS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-29
- Letzte Einreichung: 2020-09-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-18
- Letzte Einreichung: 2021-01-04
-
DUAL HOMES AND LAND LIMITED Firmenbeschreibung
- DUAL HOMES AND LAND LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC465979. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.12.2013 registriert. DUAL HOMES AND LAND LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FSTEER HOLDINGS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 272 Bath Street erreicht werden.
Jetzt sichern DUAL HOMES AND LAND LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dual Homes And Land Limited - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Grossbritannien
- 2013-12-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DUAL HOMES AND LAND LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
capital-allotment-shares (2021-09-10) - SH01
-
gazette-notice-compulsory (2021-04-20) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-05-21) - DISS16(SOAS)
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-27) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-05-27) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-05-27) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-05-27) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-05-28) - DISS40
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-05-26) - PSC04
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-14) - AAMD
-
resolution (2021-09-10) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-11-24) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-11-26) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-12-10) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-12-11) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-12-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-28) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-28) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-09) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-06) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-06-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-15) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2015-10-02) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-26) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2015-01-26) - CH04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-01-24) - TM02
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-12-16) - DISS40
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-11) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-10-11) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-09-18) - TM02
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2014-09-18) - AP04
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-12-17) - NEWINC