-
ALTAR GROUP LTD - Avian House 87 Brook Street, Broughty Ferry, Dundee, DD5 1DJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC450255
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Avian House 87 Brook Street
- Broughty Ferry
- Dundee
- DD5 1DJ Avian House 87 Brook Street, Broughty Ferry, Dundee, DD5 1DJ UK
Management
- Geschäftsführung
- ANDERSON, Victoria Elizabeth
- CHAPMAN, Nial Cameron
- EDNIE, David Thomson
- MCCALLUM, Scott Douglas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.05.2013
- Alter der Firma 2013-05-17 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Scott Douglas Mccallum
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- AVIAN COMMUNICATIONS NETWORK LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800WCHZQ2HM6QG143
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-27
- Letzte Einreichung: 2021-09-13
-
ALTAR GROUP LTD Firmenbeschreibung
- ALTAR GROUP LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC450255. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.05.2013 registriert. ALTAR GROUP LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AVIAN COMMUNICATIONS NETWORK LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Avian House 87 Brook Street erreicht werden.
Jetzt sichern ALTAR GROUP LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Altar Group Ltd - Avian House 87 Brook Street, Broughty Ferry, Dundee, DD5 1DJ, Grossbritannien
- 2013-05-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALTAR GROUP LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-10-26) - SH19
-
legacy (2021-10-26) - SH20
-
legacy (2021-10-26) - CAP-SS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-18) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-24) - CS01
-
resolution (2021-10-26) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-09-29) - SH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-21) - AA
-
resolution (2020-05-29) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-23) - CS01
-
resolution (2020-09-29) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2020-09-29) - SH01
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2020-09-29) - RP04CS01
-
capital-cancellation-shares (2020-09-29) - SH06
-
memorandum-articles (2020-09-29) - MA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-26) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-16) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-02-01) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-19) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-08-11) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2017-08-11) - SH06
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-08-18) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-07) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-16) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-06) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-10-26) - SH01
-
resolution (2015-10-26) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2015-10-06) - SH06
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-12) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-06-04) - SH01
-
resolution (2015-04-29) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-13) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-10-06) - SH03
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-05-19) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-21) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-05) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-05) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-17) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-26) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-07-18) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-24) - AP01
-
incorporation-company (2013-05-17) - NEWINC