-
WINDLINE (PEATTIE) LIMITED - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC440902
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 272 Bath Street
- Glasgow
- G2 4JR
- Scotland 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- BOLTON, Michael Ross
- CORRIGAN, Jeffrey Allan
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.01.2013
- Alter der Firma 2013-01-22 11 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Close Leasing Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- WIND LINE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-14
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
-
WINDLINE (PEATTIE) LIMITED Firmenbeschreibung
- WINDLINE (PEATTIE) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC440902. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.01.2013 registriert. WINDLINE (PEATTIE) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WIND LINE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 272 Bath Street erreicht werden.
Jetzt sichern WINDLINE (PEATTIE) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Windline (Peattie) Limited - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland, Grossbritannien
- 2013-01-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WINDLINE (PEATTIE) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-07-06) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-07) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-06) - PSC05
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-31) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-12) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-05) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-05) - MR04
-
resolution (2018-05-18) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2018-05-18) - MA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-29) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-19) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-15) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-15) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-11-30) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-29) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-29) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-29) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-29) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-11-28) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-28) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-25) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-22) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-22) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-04-28) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-21) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-30) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-17) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-07-07) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-27) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-22) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-09-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-made-up-date (2014-10-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2013-08-05) - CH04
-
certificate-change-of-name-company (2013-03-01) - CERTNM
-
incorporation-company (2013-01-22) - NEWINC