-
LOXLEY ABERDEEN LIMITED - 100, Union Street, Aberdeen, AB10 1QR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC437853
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 100
- Union Street
- Aberdeen
- AB10 1QR 100, Union Street, Aberdeen, AB10 1QR UK
Management
- Geschäftsführung
- LOGGIE, Jack William
- LOGGIE, Michael David
- Prokuristen
- KEENAN, Bryan Angus
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.11.2012
- Alter der Firma 2012-11-29 11 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jack William Loggie
- Mr Michael David John Loggie
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PLACE D'OR 724 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-08-31
- Letzte Einreichung: 2019-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-04-16
- Letzte Einreichung: 2019-04-02
-
LOXLEY ABERDEEN LIMITED Firmenbeschreibung
- LOXLEY ABERDEEN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC437853. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.11.2012 registriert. LOXLEY ABERDEEN LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PLACE D'OR 724 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 100 erreicht werden.
Jetzt sichern LOXLEY ABERDEEN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Loxley Aberdeen Limited - 100, Union Street, Aberdeen, AB10 1QR, Grossbritannien
- 2012-11-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LOXLEY ABERDEEN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-19) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-03-18) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-02) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-01) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-05) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-02) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-05) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-05) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-05) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-30) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2015-12-15) - RP04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-10) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-15) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-29) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-03-26) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2013-03-26) - CERTNM
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-03-26) - AP03
-
capital-allotment-shares (2013-03-28) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-03-26) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
resolution (2012-12-03) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2012-11-29) - NEWINC