-
FOCUS SCOTLAND TECHNOLOGY LTD - 4 North Guildry Street, Elgin, Morayshire, IV30 1JR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC437191
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 North Guildry Street
- Elgin
- Morayshire
- IV30 1JR 4 North Guildry Street, Elgin, Morayshire, IV30 1JR UK
Management
- Geschäftsführung
- CONTI, Mark Andrew
- ELDER, John Scott
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.11.2012
- Alter der Firma 2012-11-20 11 Jahre
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mark Andrew Conti
- Mr John Scott Elder
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Ehemalige Namen
- SCOTHUB LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-06-30
- Letzte Einreichung: 2021-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-08
- Letzte Einreichung: 2023-01-25
-
FOCUS SCOTLAND TECHNOLOGY LTD Firmenbeschreibung
- FOCUS SCOTLAND TECHNOLOGY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC437191. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.11.2012 registriert. FOCUS SCOTLAND TECHNOLOGY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SCOTHUB LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 4 North Guildry Street erreicht werden.
Jetzt sichern FOCUS SCOTLAND TECHNOLOGY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Focus Scotland Technology Ltd - 4 North Guildry Street, Elgin, Morayshire, IV30 1JR, Grossbritannien
- 2012-11-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FOCUS SCOTLAND TECHNOLOGY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-02-03) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2023-08-29) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-09-09) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2018-01-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-07-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-30) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-29) - PSC09
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-29) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-09-06) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-23) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-12-17) - DISS40
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2016-10-08) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-16) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-25) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-11-28) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2015-10-16) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-22) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-12) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-12) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-10-06) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-10-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-03) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-08-01) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2014-05-27) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-11-21) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-11-21) - AA01
-
incorporation-company (2012-11-20) - NEWINC