-
EQUITIX ENERGY EFFICIENT EPS GP 1 LIMITED - Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5HD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC428478
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Citypoint
- 65 Haymarket Terrace
- Edinburgh
- EH12 5HD
- Scotland Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5HD, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- CROSSLEY, Hugh Barnabas
- CÔTE, Sean Andrew
- JACKSON, Geoffrey Allan
- ROUGHTON, Peter Sandor
- SMITH, Jonathan Charles
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-17 11 Jahre
- SIC/NACE
- 66300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Equitix Holdings Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-07-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2020-07-17
-
EQUITIX ENERGY EFFICIENT EPS GP 1 LIMITED Firmenbeschreibung
- EQUITIX ENERGY EFFICIENT EPS GP 1 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC428478. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.07.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66300" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.07.2013.Die Firma kann schriftlich über Citypoint erreicht werden.
Jetzt sichern EQUITIX ENERGY EFFICIENT EPS GP 1 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Equitix Energy Efficient Eps Gp 1 Limited - Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5HD, Grossbritannien
- 2012-07-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EQUITIX ENERGY EFFICIENT EPS GP 1 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-07-09) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-11-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-08-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-22) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-15) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-24) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-12-21) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-09) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-28) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-28) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-08-28) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-19) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-17) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-07) - CS01
-
resolution (2016-02-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
auditors-resignation-company (2015-10-08) - AUD
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-08) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-06-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-18) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-05-01) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-17) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-01) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-17) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-19) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-07-25) - AA01
-
incorporation-company (2012-07-17) - NEWINC