-
CARBOMAP LIMITED - 5 West View, Linlithgow Bridge, Linlithgow, EH49 7RB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC416482
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 West View
- Linlithgow Bridge
- Linlithgow
- EH49 7RB
- Scotland 5 West View, Linlithgow Bridge, Linlithgow, EH49 7RB, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- WOODHOUSE, Iain Hector, Prof
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-08 12 Jahre
- SIC/NACE
- 02400
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Prof Iain Hector Woodhouse
- Edinburgh Technology Fund Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-10
- Letzte Einreichung: 2024-02-24
-
CARBOMAP LIMITED Firmenbeschreibung
- CARBOMAP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC416482. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "02400" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.02.2013.Die Firma kann schriftlich über 5 West View erreicht werden.
Jetzt sichern CARBOMAP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Carbomap Limited - 5 West View, Linlithgow Bridge, Linlithgow, EH49 7RB, Grossbritannien
- 2012-02-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CARBOMAP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-03-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-20) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-12) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-15) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-19) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-11) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-08) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-24) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-19) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-01) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-03-05) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-11-17) - AA01
-
capital-allotment-shares (2014-10-10) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-04) - AR01
-
resolution (2013-07-04) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-07-04) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2013-11-04) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-13) - TM01
-
incorporation-company (2012-02-08) - NEWINC