-
COOK & CO LIMITED - Abercorn House, 79 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC407467
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Abercorn House
- 79 Renfrew Road
- Paisley
- Renfrewshire
- PA3 4DA
- Scotland Abercorn House, 79 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DA, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- BROWN, Katherine
- BUTLER, Craig Gordon
- CRAIG, Paul
- NAIRN, David Hamilton
- PARBROOK, Donald Henry
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.09.2011
- Alter der Firma 2011-09-14 13 Jahre
- SIC/NACE
- 69201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Milne Craig Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-09-30
- Letzte Einreichung: 2012-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-28
- Letzte Einreichung: 2023-09-14
-
COOK & CO LIMITED Firmenbeschreibung
- COOK & CO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC407467. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.09.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69201" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Abercorn House erreicht werden.
Jetzt sichern COOK & CO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cook & Co Limited - Abercorn House, 79 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, Grossbritannien
- 2011-09-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COOK & CO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2024-07-19) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-05-23) - MR04
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-11-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-09-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-09) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-30) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-06-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-14) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-26) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-26) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-07-26) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-23) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-21) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-21) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-21) - PSC02
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-27) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-27) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-09-26) - AA
-
capital-cancellation-shares (2017-01-16) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-01-16) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-14) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-06-14) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-11-27) - MG01s
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-09-14) - NEWINC