-
PRG (NORTH) LIMITED - 29 Brandon Street, Hamilton, South Lanarkshire, ML3 6DA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC401765
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 29 Brandon Street
- Hamilton
- South Lanarkshire
- ML3 6DA 29 Brandon Street, Hamilton, South Lanarkshire, ML3 6DA UK
Management
- Geschäftsführung
- ROBERTSON, James Reid
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.06.2011
- Gelöscht am:
- 2023-11-28
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Walter Kidd Gray
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- M.T.S. DUNROBIN LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-12
- Letzte Einreichung: 2023-06-28
-
PRG (NORTH) LIMITED Firmenbeschreibung
- PRG (NORTH) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC401765. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.06.2011 registriert. PRG (NORTH) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen M.T.S. DUNROBIN LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 29 Brandon Street erreicht werden.
Jetzt sichern PRG (NORTH) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Prg (North) Limited - 29 Brandon Street, Hamilton, South Lanarkshire, ML3 6DA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PRG (NORTH) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-voluntary (2023-11-28) - GAZ2(A)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-02) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-09-04) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2023-09-12) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-12-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-28) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-25) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-06-25) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-24) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-03) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-09-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-10-20) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-20) - AP01
-
capital-allotment-shares (2019-05-31) - SH01
-
capital-allotment-shares (2019-05-23) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-13) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-27) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-06-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-15) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-24) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-10-20) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-23) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-03) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-03-30) - AA
-
capital-allotment-shares (2015-10-24) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-02-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-06-15) - NEWINC