-
CRIEFF VETS LIMITED - C/O Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, AB15 4YL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC395262
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Pinsent Masons Llp
- 13 Queens Road
- Aberdeen
- AB15 4YL
- Scotland C/O Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, AB15 4YL, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- CHAPMAN, Donna Louise
- GILLINGS, Mark Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.03.2011
- Alter der Firma 2011-03-11 13 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Independent Vetcare Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-06-30
- Letzte Einreichung: 2021-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-03-25
- Letzte Einreichung: 2022-03-11
-
CRIEFF VETS LIMITED Firmenbeschreibung
- CRIEFF VETS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC395262. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.03.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.03.2013.Die Firma kann schriftlich über C/o Pinsent Masons Llp erreicht werden.
Jetzt sichern CRIEFF VETS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Crieff Vets Limited - C/O Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, AB15 4YL, Grossbritannien
- 2011-03-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CRIEFF VETS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-04-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-04-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-25) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-10-25) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-06-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-28) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-02) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-12) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-06-24) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-02) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-21) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-26) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-13) - AA01
-
resolution (2018-01-05) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-20) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-20) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-20) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-20) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-12-09) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-07-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-17) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-13) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-10) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-01-27) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-03-31) - MG01s
-
incorporation-company (2011-03-11) - NEWINC