-
FIBREREACH LTD. - Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC380475
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Quartermile One
- 15 Lauriston Place
- Edinburgh
- EH3 9EP Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EP UK
Management
- Geschäftsführung
- WALLACE, Howard William Innes
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.06.2010
- Gelöscht am:
- 2023-08-22
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Howard William Innes Wallace
- Mr John Alexander Petrie
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-06-16
-
FIBREREACH LTD. Firmenbeschreibung
- FIBREREACH LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC380475. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Quartermile One erreicht werden.
Jetzt sichern FIBREREACH LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fibrereach Ltd. - Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FIBREREACH LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-voluntary (2023-08-22) - GAZ2(A)
-
gazette-notice-voluntary (2023-06-06) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-05-25) - DS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-17) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-17) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-03) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-19) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-02-04) - AA01
-
capital-allotment-shares (2014-08-29) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-01) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-08-09) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-08-09) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-03) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-02-03) - AP03
-
capital-allotment-shares (2011-02-03) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-08) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-02-08) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-24) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-12-12) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-02-08) - AP03
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-secretary-company-with-name (2010-06-21) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-06-21) - TM01
-
incorporation-company (2010-06-16) - NEWINC