-
ALBATERN LIMITED - Midlothian Innovation Centre, Pentlandfield, Roslin, Midlothian, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC379385
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Midlothian Innovation Centre
- Pentlandfield
- Roslin
- Midlothian
- EH25 9RE Midlothian Innovation Centre, Pentlandfield, Roslin, Midlothian, EH25 9RE UK
Management
- Geschäftsführung
- CAMPBELL, David James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.05.2010
- Alter der Firma 2010-05-28 14 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Donald Francis Irwin Houston
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- WAVENET ENERGY LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-11
- Letzte Einreichung: 2020-05-28
-
ALBATERN LIMITED Firmenbeschreibung
- ALBATERN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC379385. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.05.2010 registriert. ALBATERN LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WAVENET ENERGY LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.05.2012.Die Firma kann schriftlich über Midlothian Innovation Centre erreicht werden.
Jetzt sichern ALBATERN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Albatern Limited - Midlothian Innovation Centre, Pentlandfield, Roslin, Midlothian, Grossbritannien
- 2010-05-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALBATERN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-06-18) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-05-25) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-11) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-11) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-11) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-04-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-20) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-24) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-01-28) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-02) - MR01
-
resolution (2015-01-28) - RESOLUTIONS
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2015-09-30) - 466(Scot)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-23) - AA
-
resolution (2015-07-09) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-07-25) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-03-02) - SH01
-
resolution (2011-03-02) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2011-03-03) - SH02
-
capital-allotment-shares (2011-03-03) - SH01
-
resolution (2011-03-03) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-06-27) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-27) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-06) - AP01
-
resolution (2011-10-10) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2011-10-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-of-name-request-comments (2010-07-21) - NM06
-
certificate-change-of-name-company (2010-07-21) - CERTNM
-
resolution (2010-07-21) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2010-05-28) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-07-15) - AP01