-
CORNEL LOGISTIC LTD - Suite 2 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, ML11 0QW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC368372
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 2 44 Main Street
- Douglas
- South Lanarkshire
- ML11 0QW
- Scotland Suite 2 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, ML11 0QW, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- OLES, Jozef
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.11.2009
- Gelöscht am:
- 2023-07-25
- SIC/NACE
- 52290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr. Eduards Slobins
- Mr Jozef Oles
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-08-31
- Letzte Einreichung: 2018-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-11
-
CORNEL LOGISTIC LTD Firmenbeschreibung
- CORNEL LOGISTIC LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC368372. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.11.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52290" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite 2 44 Main Street erreicht werden.
Jetzt sichern CORNEL LOGISTIC LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cornel Logistic Ltd - Suite 2 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, ML11 0QW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CORNEL LOGISTIC LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-compulsory (2023-07-25) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-notice-compulsory (2021-04-06) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-05-14) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-04-16) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-11-27) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-10-29) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-21) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-10-12) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-03-21) - TM02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-27) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-27) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-11-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-13) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-11-27) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-13) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-29) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-26) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-17) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-10-17) - AAMD
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-05) - AD01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-09) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-08-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-09-14) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-02-09) - AAMD
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-13) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-11-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-12-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-07) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-01) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-09-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-11-11) - NEWINC