-
FOUR CHAPEL STREET LTD - 56, Palmerston Place, Edinburgh, EH12 5AY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC366748
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 56
- Palmerston Place
- Edinburgh
- EH12 5AY 56, Palmerston Place, Edinburgh, EH12 5AY UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.10.2009
- Gelöscht am:
- 2020-11-26
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Carl Henning Hansen
- Mrs Robin Hansen
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- RTTCH LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-07-31
- Letzte Einreichung: 2016-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-10-15
- Letzte Einreichung: 2017-10-01
-
FOUR CHAPEL STREET LTD Firmenbeschreibung
- FOUR CHAPEL STREET LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC366748. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 13.10.2009 registriert. FOUR CHAPEL STREET LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RTTCH LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2016 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 56 erreicht werden.
Jetzt sichern FOUR CHAPEL STREET LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Four Chapel Street Ltd - 56, Palmerston Place, Edinburgh, EH12 5AY, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FOUR CHAPEL STREET LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-compulsory-return-final-meeting-court-scotland (2020-08-26) - WU15(Scot)
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-compulsory-notice-winding-up-order-court-scotland (2019-06-10) - WU01(Scot)
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-28) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-28) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-28) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-25) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2018-09-25) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-10-24) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-16) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-18) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-22) - AR01
-
administrative-restoration-company (2016-08-22) - RT01
-
gazette-dissolved-compulsory (2016-03-29) - GAZ2
-
gazette-notice-compulsory (2016-01-12) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-22) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-23) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-04-26) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-25) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-11) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-12-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-26) - AR01
-
administrative-restoration-company (2013-06-26) - RT01
-
gazette-dissolved-compulsary (2013-06-07) - GAZ2
-
gazette-notice-compulsary (2013-02-15) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-07-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-01-20) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-01-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-05-17) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2011-01-20) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-13) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-13) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-02-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
certificate-change-of-name-company (2009-12-11) - CERTNM
-
resolution (2009-12-11) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name (2009-10-23) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2009-10-21) - TM01
-
incorporation-company (2009-10-13) - NEWINC