-
CANONGATE DESIGN LIMITED - Crookston Cottage 5 Cookston Road, Inveresk, Musselburgh, East Lothian, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC360372
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Crookston Cottage 5 Cookston Road
- Inveresk
- Musselburgh
- East Lothian
- EH21 7TQ Crookston Cottage 5 Cookston Road, Inveresk, Musselburgh, East Lothian, EH21 7TQ UK
Management
- Geschäftsführung
- CRAIG, Kenneth James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.05.2009
- Alter der Firma 2009-05-28 15 Jahre
- SIC/NACE
- 74100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Sandra Anne Craig
- Mr Kenneth James Craig
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- GRAPHIC PARTNERS EDINBURGH LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-02-29
- Letzte Einreichung: 2022-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-11
- Letzte Einreichung: 2022-05-28
-
CANONGATE DESIGN LIMITED Firmenbeschreibung
- CANONGATE DESIGN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC360372. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.05.2009 registriert. CANONGATE DESIGN LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GRAPHIC PARTNERS EDINBURGH LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.05.2012.Die Firma kann schriftlich über Crookston Cottage 5 Cookston Road erreicht werden.
Jetzt sichern CANONGATE DESIGN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Canongate Design Limited - Crookston Cottage 5 Cookston Road, Inveresk, Musselburgh, East Lothian, Grossbritannien
- 2009-05-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CANONGATE DESIGN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-05-03) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-08) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-28) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-08) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-06-05) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-01) - AR01
-
resolution (2013-06-05) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-05) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-06-05) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-06-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-02) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-25) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-10-01) - TM02
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2010-10-01) - AP04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-11-06) - AD01
-
legacy (2009-06-15) - 288b
-
legacy (2009-06-15) - 288a
-
incorporation-company (2009-05-28) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2009-06-03) - CERTNM