-
KI CONTRACTS LIMITED - 11 Youngs Road, East Mains Industrial Estate, Broxburn, West Lothian, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC356562
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11 Youngs Road
- East Mains Industrial Estate
- Broxburn
- West Lothian
- EH52 5LY 11 Youngs Road, East Mains Industrial Estate, Broxburn, West Lothian, EH52 5LY UK
Management
- Geschäftsführung
- O'BRIEN, Paul Gerard
- STEPHEN, Charles Milne Cameron
- WATSON, Gerald William
- Prokuristen
- WATSON, Gerald William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.03.2009
- Alter der Firma 2009-03-13 15 Jahre
- SIC/NACE
- 47599
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Kitchens International Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-27
- Letzte Einreichung: 2021-03-13
-
KI CONTRACTS LIMITED Firmenbeschreibung
- KI CONTRACTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC356562. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.03.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47599" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.03.2013.Die Firma kann schriftlich über 11 Youngs Road erreicht werden.
Jetzt sichern KI CONTRACTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ki Contracts Limited - 11 Youngs Road, East Mains Industrial Estate, Broxburn, West Lothian, Grossbritannien
- 2009-03-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KI CONTRACTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-05-27) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-15) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-05-26) - PSC07
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-04-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-13) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-07) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2019-02-07) - CH03
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-04-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-14) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-14) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-14) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-06-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-07) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-06-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-05-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-04-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-05-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-09-01) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-05-05) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-27) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-04-21) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-04-19) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
termination-secretary-company-with-name (2009-12-22) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2009-12-22) - AP03
-
legacy (2009-03-31) - 225
-
incorporation-company (2009-03-13) - NEWINC