-
SCOTTISH LEGAL NEWS LIMITED - Kinburn Castle, Double Dykes Road, St. Andrews, Fife, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC343805
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Kinburn Castle
- Double Dykes Road
- St. Andrews
- Fife
- KY16 9DR Kinburn Castle, Double Dykes Road, St. Andrews, Fife, KY16 9DR UK
Management
- Geschäftsführung
- GRANT-HUTCHISON, Peter Alexander
- KEANE, Eamon
- OGILVY, Graham John
- SUTHERLAND, Robert David
- Prokuristen
- THORNTONS LAW LLP
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.06.2008
- Alter der Firma 2008-06-03 15 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Graham John Ogilvy
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-26
- Letzte Einreichung: 2020-03-12
-
SCOTTISH LEGAL NEWS LIMITED Firmenbeschreibung
- SCOTTISH LEGAL NEWS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC343805. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.06.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Kinburn Castle erreicht werden.
Jetzt sichern SCOTTISH LEGAL NEWS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Scottish Legal News Limited - Kinburn Castle, Double Dykes Road, St. Andrews, Fife, Grossbritannien
- 2008-06-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SCOTTISH LEGAL NEWS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-12) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-01-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-22) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-22) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-20) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-06) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-06-03) - TM02
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-06-03) - AP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-11) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-15) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-03) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2013-07-03) - CH04
-
termination-director-company-with-name (2013-07-03) - TM01
-
resolution (2013-06-12) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-27) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-08-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-28) - AR01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2011-09-27) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name (2011-09-27) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-21) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-09-14) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-05-05) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-06-11) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-02) - 288a
-
legacy (2008-08-27) - 88(2)
-
legacy (2008-06-27) - 288a
-
legacy (2008-06-27) - 288b
-
incorporation-company (2008-06-03) - NEWINC