-
MENZIES SOFTWARE LIMITED - 272 Bath Street, Glasgow, Lanarkshire, G2 4JR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC325101
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 272 Bath Street
- Glasgow
- Lanarkshire
- G2 4JR 272 Bath Street, Glasgow, Lanarkshire, G2 4JR UK
Management
- Geschäftsführung
- MENZIES, Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.06.2007
- Alter der Firma 2007-06-07 16 Jahre
- SIC/NACE
- 62090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Menzies
- Mr Paul Menzies
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-21
- Letzte Einreichung: 2020-06-07
-
MENZIES SOFTWARE LIMITED Firmenbeschreibung
- MENZIES SOFTWARE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC325101. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.06.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 272 Bath Street erreicht werden.
Jetzt sichern MENZIES SOFTWARE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Menzies Software Limited - 272 Bath Street, Glasgow, Lanarkshire, G2 4JR, Grossbritannien
- 2007-06-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MENZIES SOFTWARE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-04-22) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-02-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-15) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-21) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-09) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-secretary-company-with-name (2014-06-20) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-02-21) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-22) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-21) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-07-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-22) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-06-27) - 363a
-
legacy (2009-06-27) - 288c
-
legacy (2009-03-25) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-03) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-06-07) - NEWINC