-
SCOTT HAMPERS LTD - HARRIS DONALD, 82 West Nile Street, Glasgow, G1 2QH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC305544
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- HARRIS DONALD
- 82 West Nile Street
- Glasgow
- G1 2QH HARRIS DONALD, 82 West Nile Street, Glasgow, G1 2QH UK
Management
- Geschäftsführung
- JENKINS, Russell Christopher
- JENKINS, Stuart Nicol
- Prokuristen
- JENKINS, Stuart Nicol
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.07.2006
- Gelöscht am:
- 2021-01-05
- SIC/NACE
- 47290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Scott Mccormick
- Scott Mccormick
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- SCOTT MCCORMICK MEDIEVAL BANQUETS LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2018-07-30
-
SCOTT HAMPERS LTD Firmenbeschreibung
- SCOTT HAMPERS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC305544. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 17.07.2006 registriert. SCOTT HAMPERS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SCOTT MCCORMICK MEDIEVAL BANQUETS LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47290" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.07.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Harris Donald erreicht werden.
Jetzt sichern SCOTT HAMPERS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Scott Hampers Ltd - HARRIS DONALD, 82 West Nile Street, Glasgow, G1 2QH, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SCOTT HAMPERS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-compulsory (2021-01-05) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-10-20) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-11-03) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-31) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-10-09) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-27) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-26) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-01-25) - PSC09
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-11) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-01-11) - CH03
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-21) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-25) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-04-29) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-05) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-19) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-02-26) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-26) - AA
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2013-02-26) - RP04
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-13) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-06) - AA
-
legacy (2012-02-29) - MG01s
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-20) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-10-04) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-04) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-04) - 363a
-
legacy (2009-07-14) - 288a
-
legacy (2009-07-14) - 288b
-
legacy (2009-07-14) - 88(2)
-
legacy (2009-08-29) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-04) - AA
-
legacy (2009-08-29) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-06) - 288a
-
certificate-change-of-name-company (2008-10-24) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-08-30) - 363s
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-10-16) - 288a
-
legacy (2006-10-06) - 225
-
legacy (2006-10-06) - 288a
-
legacy (2006-07-19) - 288b
-
incorporation-company (2006-07-17) - NEWINC