-
DEN DER SOVER LIMITED - 25 Bothwell Street, Glasgow, G2 6NL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC281737
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25 Bothwell Street
- Glasgow
- G2 6NL 25 Bothwell Street, Glasgow, G2 6NL UK
Management
- Geschäftsführung
- KJAERHAUGE, Anders Serup
- WELLS, Sarah Ann
- Prokuristen
- SCOTT-MONCRIEFF
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.03.2005
- Gelöscht am:
- 2021-03-16
- SIC/NACE
- 59111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Anders Serup Kjaerhauge
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- SIGMA FILMS (THE ONE THAT SLEEPS) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-11
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
-
DEN DER SOVER LIMITED Firmenbeschreibung
- DEN DER SOVER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC281737. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 18.03.2005 registriert. DEN DER SOVER LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SIGMA FILMS (THE ONE THAT SLEEPS) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.03.2013.Die Firma kann schriftlich über 25 Bothwell Street erreicht werden.
Jetzt sichern DEN DER SOVER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Den Der Sover Limited - 25 Bothwell Street, Glasgow, G2 6NL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DEN DER SOVER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-12-22) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-12) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-12-16) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-04) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-04) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-18) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-04) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-04) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-14) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-10-14) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-07) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-31) - AA
-
legacy (2009-04-16) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-05) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-07-31) - AA
-
legacy (2008-06-20) - 363s
-
legacy (2008-03-12) - 288a
-
legacy (2008-03-12) - 288b
-
legacy (2008-02-27) - 288c
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-06-05) - 288a
-
legacy (2007-06-27) - 363a
-
legacy (2007-07-12) - 288c
-
legacy (2007-09-07) - 288b
-
legacy (2007-11-22) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-11-29) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-07-27) - AA
-
legacy (2006-07-26) - 410(Scot)
-
legacy (2006-04-24) - 363s
-
legacy (2006-02-15) - 288c
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-06-09) - 225
-
certificate-change-of-name-company (2005-05-31) - CERTNM
-
legacy (2005-05-06) - 288a
-
legacy (2005-04-04) - 288a
-
legacy (2005-04-04) - 288b
-
incorporation-company (2005-03-18) - NEWINC