-
G M MORTGAGE BROKERS LTD. - 7 The Marches, Armadale, Bathgate, West Lothian, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC258128
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 7 The Marches
- Armadale
- Bathgate
- West Lothian
- EH48 2PG 7 The Marches, Armadale, Bathgate, West Lothian, EH48 2PG UK
Management
- Geschäftsführung
- BLACKLEY, Micheal
- HEMMINGS, Brian Alexander
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.10.2003
- Gelöscht am:
- 2020-02-25
- SIC/NACE
- 66220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Gmb Portfolio Services Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-23
-
G M MORTGAGE BROKERS LTD. Firmenbeschreibung
- G M MORTGAGE BROKERS LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC258128. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.10.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66220" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 7 The Marches erreicht werden.
Jetzt sichern G M MORTGAGE BROKERS LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: G M Mortgage Brokers Ltd. - 7 The Marches, Armadale, Bathgate, West Lothian, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu G M MORTGAGE BROKERS LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-02-25) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-19) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-19) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-19) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-19) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-09-19) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-23) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-07) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-11) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-16) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2009-11-16) - CH03
-
termination-director-company-with-name (2009-11-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-11) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-02-04) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-25) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-05-03) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-01-05) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-02-10) - AA
-
legacy (2006-11-17) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-11-16) - 287
-
legacy (2004-11-15) - 363s
-
legacy (2004-02-09) - 225
-
legacy (2004-02-09) - 288a
-
legacy (2004-01-09) - 288a
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-10-31) - 288b
-
incorporation-company (2003-10-23) - NEWINC