-
M.M.M.I.T. CONSULTING LTD. - 4th, Floor 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC241119
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th
- Floor 58 Waterloo Street
- Glasgow
- G2 7DA 4th, Floor 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA UK
Management
- Geschäftsführung
- MCMILLAN, Helen Margaret
- Prokuristen
- MCMILLAN, Helen Margaret
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.12.2002
- Gelöscht am:
- 2020-06-26
- SIC/NACE
- 63990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Helen Margaret Mcmillan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-06-05
- Letzte Einreichung: 2017-09-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-12-27
- Letzte Einreichung: 2018-12-13
-
M.M.M.I.T. CONSULTING LTD. Firmenbeschreibung
- M.M.M.I.T. CONSULTING LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC241119. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 13.12.2002 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "63990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 05/04/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4Th erreicht werden.
Jetzt sichern M.M.M.I.T. CONSULTING LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: M.m.m.i.t. Consulting Ltd. - 4th, Floor 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu M.M.M.I.T. CONSULTING LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting-scotland (2020-03-26) - LIQ13(Scot)
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-03-16) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-05) - AD01
-
resolution (2019-04-04) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-15) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-10-24) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-10-13) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-02) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-27) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-15) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-22) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-16) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-10-29) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-01-10) - AA
-
legacy (2008-01-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-14) - 363a
-
legacy (2006-02-09) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-02-17) - 410(Scot)
-
legacy (2005-04-14) - 410(Scot)
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-12-15) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-10-12) - AA
-
legacy (2004-01-07) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-05-28) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-12-23) - 225
-
legacy (2002-12-23) - 288a
-
legacy (2002-12-19) - 288b
-
legacy (2002-12-17) - 288b
-
incorporation-company (2002-12-13) - NEWINC