-
BDL NOMINEES LIMITED - 40 Brand Street, Glasgow, G51 1DG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC212247
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 40 Brand Street
- Glasgow
- G51 1DG 40 Brand Street, Glasgow, G51 1DG UK
Management
- Geschäftsführung
- CAMPBELL, Stewart
- MCCAFFER, Stuart John
- Prokuristen
- MCCAFFER, Stuart John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.10.2000
- Gelöscht am:
- 2020-09-22
- SIC/NACE
- 70221
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Stuart John Mccaffer
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- PACIFIC SHELF 999 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-21
- Letzte Einreichung: 2019-10-10
-
BDL NOMINEES LIMITED Firmenbeschreibung
- BDL NOMINEES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC212247. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 24.10.2000 registriert. BDL NOMINEES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PACIFIC SHELF 999 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70221" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 40 Brand Street erreicht werden.
Jetzt sichern BDL NOMINEES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bdl Nominees Limited - 40 Brand Street, Glasgow, G51 1DG, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BDL NOMINEES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-09-22) - GAZ2(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-06-29) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-07-07) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-11-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-11-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-18) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-28) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-28) - PSC09
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-07-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-31) - AA
-
resolution (2014-07-30) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-23) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2012-09-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2012-09-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-03) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-03-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-02-28) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-03-09) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-23) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-20) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-15) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-09-01) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-01) - 287
-
legacy (2007-10-16) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2007-05-01) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-10-24) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-10-10) - 363a
-
legacy (2005-09-12) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2005-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2004-11-22) - AA
-
legacy (2004-10-28) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2004-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-11-04) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-full (2003-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-11-26) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-full (2002-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2001
-
legacy (2001-11-26) - 363s
keyboard_arrow_right 2000
-
legacy (2000-12-06) - 288a
-
legacy (2000-12-06) - 288b
-
incorporation-company (2000-10-24) - NEWINC
-
legacy (2000-12-06) - 287
-
certificate-change-of-name-company (2000-12-11) - CERTNM