-
OVERFINGLAND NOMINEES LIMITED - 66 Albion Road, Edinburgh, EH7 5QZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC198372
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 66 Albion Road
- Edinburgh
- EH7 5QZ 66 Albion Road, Edinburgh, EH7 5QZ UK
Management
- Geschäftsführung
- WEATHERALL, Benjamin Joseph Keswick
- Prokuristen
- WEATHERALL, Benjamin Joseph Keswick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.07.1999
- Gelöscht am:
- 2020-07-20
- SIC/NACE
- 64205
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Benjamin Joseph Keswick Weatherall
- Mr Edward Percy Keswick Weatherall
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- PORTBREEZE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2017-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-26
-
OVERFINGLAND NOMINEES LIMITED Firmenbeschreibung
- OVERFINGLAND NOMINEES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC198372. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 26.07.1999 registriert. OVERFINGLAND NOMINEES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PORTBREEZE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64205" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 66 Albion Road erreicht werden.
Jetzt sichern OVERFINGLAND NOMINEES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Overfingland Nominees Limited - 66 Albion Road, Edinburgh, EH7 5QZ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OVERFINGLAND NOMINEES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-07-20) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting-scotland (2020-04-20) - LIQ13(Scot)
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-08-15) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-02) - TM01
-
legacy (2018-02-19) - RP04CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-31) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-01-24) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-14) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-04) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-08-21) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-01) - AA
-
legacy (2009-08-05) - 363a
-
legacy (2009-08-05) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-14) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-30) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-09-07) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-09-18) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-08-25) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-08-09) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-09-14) - AA
-
legacy (2004-08-02) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2003-09-03) - AA
-
legacy (2003-07-24) - 363s
keyboard_arrow_right 2002
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2002-09-10) - AA
-
legacy (2002-08-06) - 363s
keyboard_arrow_right 2001
-
legacy (2001-07-31) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-small (2001-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2000
-
legacy (2000-08-08) - 363s
keyboard_arrow_right 1999
-
memorandum-articles (1999-10-06) - MEM/ARTS
-
legacy (1999-10-06) - 288b
-
legacy (1999-10-06) - 288a
-
legacy (1999-10-06) - 287
-
resolution (1999-10-05) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (1999-08-26) - CERTNM
-
legacy (1999-10-06) - 225
-
incorporation-company (1999-07-26) - NEWINC