-
AMERICOLD HOLDINGS UK LIMITED - 66 Silverwood Industrial Area, Silverwood Road, Lurgan, Armagh, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI633567
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 66 Silverwood Industrial Area
- Silverwood Road
- Lurgan
- Armagh
- BT66 6LN 66 Silverwood Industrial Area, Silverwood Road, Lurgan, Armagh, BT66 6LN UK
Management
- Geschäftsführung
- SMERNOFF, Marc Jason
- SNYDER, JR, James Conrad
- WINNALL, Richard Charles
- YUEN, Che Lup
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.09.2015
- Alter der Firma 2015-09-11 8 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Oaktree Capital Group, Llc
- Agro Merchants Latam Holdings S.A.R.L.
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- AGRO MERCHANTS HOLDINGS UK LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2017-09-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-18
- Letzte Einreichung: 2022-09-04
-
AMERICOLD HOLDINGS UK LIMITED Firmenbeschreibung
- AMERICOLD HOLDINGS UK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI633567. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.09.2015 registriert. AMERICOLD HOLDINGS UK LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AGRO MERCHANTS HOLDINGS UK LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.09.2017.Die Firma kann schriftlich über 66 Silverwood Industrial Area erreicht werden.
Jetzt sichern AMERICOLD HOLDINGS UK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Americold Holdings Uk Limited - 66 Silverwood Industrial Area, Silverwood Road, Lurgan, Armagh, Grossbritannien
- 2015-09-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AMERICOLD HOLDINGS UK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-02-28) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-03-11) - DISS40
keyboard_arrow_right 2022
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-03-23) - CH01
-
capital-allotment-shares (2022-06-09) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-06-09) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-06-09) - PSC07
-
second-filing-capital-allotment-shares (2022-12-23) - RP04SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-10-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-09-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-10-04) - AP01
-
capital-allotment-shares (2022-12-21) - SH01
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2022-12-21) - RP04CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
certificate-change-of-name-company (2021-11-08) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-10-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-13) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-03-22) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-22) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-05) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-01-07) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-28) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-19) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-06) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-27) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-08) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-12-13) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-11) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-01-11) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2016-01-11) - MA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-23) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-21) - CS01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-09-21) - AD02
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-22) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-17) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-09-16) - AA01
-
incorporation-company (2015-09-11) - NEWINC