-
WARING STREET LIMITED - 41-43 Waring Street, Belfast, County Antrim, BT1 2DY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI627837
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 41-43 Waring Street
- Belfast
- County Antrim
- BT1 2DY 41-43 Waring Street, Belfast, County Antrim, BT1 2DY UK
Management
- Geschäftsführung
- MARSHALL, David Frederick Edwin
- SANDY, Colin Torquil
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.11.2014
- Alter der Firma 2014-11-17 9 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Norlin Trading No1 Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- KILLER INVESTMENTS LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800A54LLJYGGCCX97
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-28
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-24
- Letzte Einreichung: 2021-04-10
-
WARING STREET LIMITED Firmenbeschreibung
- WARING STREET LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI627837. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.11.2014 registriert. WARING STREET LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen KILLER INVESTMENTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 41-43 Waring Street erreicht werden.
Jetzt sichern WARING STREET LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Waring Street Limited - 41-43 Waring Street, Belfast, County Antrim, BT1 2DY, Grossbritannien
- 2014-11-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WARING STREET LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-14) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-08-03) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-26) - AA
-
resolution (2019-08-20) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-08) - TM01
-
memorandum-articles (2019-11-11) - MA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-10) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-10) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-10) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-11) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-16) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-07-23) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-18) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-10) - PSC02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-03) - MR04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-24) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-23) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-10) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-04-10) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-03) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-03) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-03-11) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-11) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-01) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-07-18) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-04) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-03-15) - TM02
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-19) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-20) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2015-07-06) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-03) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-04-01) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-01) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-31) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-23) - AR01
-
incorporation-company (2014-11-17) - NEWINC