-
PRECISION LIVESTOCK MEASUREMENT LIMITED - 97 Moy Road Moy Road, Dungannon, BT71 7DX, Northern Ireland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI624778
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 97 Moy Road Moy Road
- Dungannon
- BT71 7DX
- Northern Ireland 97 Moy Road Moy Road, Dungannon, BT71 7DX, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- CONWAY, Ciaran
- MCLAUGHLIN, Patrick Anthony
- REID, Eric
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-23 10 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ni033747
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- MOYNE SHELF COMPANY (NO. 353) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-05-31
- Letzte Einreichung: 2021-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-07-21
- Letzte Einreichung: 2022-07-07
-
PRECISION LIVESTOCK MEASUREMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- PRECISION LIVESTOCK MEASUREMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI624778. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.05.2014 registriert. PRECISION LIVESTOCK MEASUREMENT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MOYNE SHELF COMPANY (NO. 353) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 97 Moy Road Moy Road erreicht werden.
Jetzt sichern PRECISION LIVESTOCK MEASUREMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Precision Livestock Measurement Limited - 97 Moy Road Moy Road, Dungannon, BT71 7DX, Northern Ireland, Grossbritannien
- 2014-05-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PRECISION LIVESTOCK MEASUREMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-05-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-02-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-23) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-07) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-10-20) - TM02
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-04) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-12-22) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-04-20) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-02-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-07-01) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-31) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-05-18) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-15) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-05-15) - TM02
-
gazette-notice-compulsory (2019-04-30) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-11) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-15) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-18) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-09) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-22) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-05-23) - NEWINC
-
change-of-name-notice (2014-10-16) - CONNOT
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-08) - AP01
-
resolution (2014-09-10) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2014-09-10) - CONNOT
-
capital-allotment-shares (2014-09-10) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-09-10) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-10) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-09-10) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-10) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2014-10-16) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-02) - AP01