-
KILLYLANE PROPERTIES LIMITED - 1-6 St. Helens Business Park, Holywood, County Down, BT18 9HQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI611348
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1-6 St. Helens Business Park
- Holywood
- County Down
- BT18 9HQ 1-6 St. Helens Business Park, Holywood, County Down, BT18 9HQ UK
Management
- Geschäftsführung
- HOBART, George Brian
- WEBB, Helen Malcolm
- WEBB, Ian William Larmor
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-23 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ian William Larmor Webb
- Mr George Brian Hobart
- John Hogg & Co Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ARLISH LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-01-31
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-03-08
- Letzte Einreichung: 2019-02-23
-
KILLYLANE PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- KILLYLANE PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI611348. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.02.2012 registriert. KILLYLANE PROPERTIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ARLISH LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.02.2013.Die Firma kann schriftlich über 1-6 St. Helens Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern KILLYLANE PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Killylane Properties Limited - 1-6 St. Helens Business Park, Holywood, County Down, BT18 9HQ, Grossbritannien
- 2012-02-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KILLYLANE PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2020-02-20) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-01-21) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-01-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-25) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-part (2017-02-07) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-05-25) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-06) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-27) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-13) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-12-15) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-02-16) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-part (2016-02-16) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-02-26) - MR04
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2016-02-22) - SH02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-12-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-12-20) - MR04
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2016-09-15) - SH02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-02) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-part (2016-08-02) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-09-01) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-09) - AA
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2015-06-11) - SH02
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2015-02-17) - SH02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2014-12-12) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-22) - AA
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2014-03-19) - SH02
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-11) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-04) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-09-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-06-12) - MG01
-
resolution (2012-06-11) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2012-06-08) - SH01
-
resolution (2012-06-08) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-28) - AP01
-
resolution (2012-03-28) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-28) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2012-03-28) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2012-03-13) - CERTNM
-
memorandum-articles (2012-07-11) - MEM/ARTS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-06-20) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-06-20) - AD01
-
incorporation-company (2012-02-23) - NEWINC