-
MMJP LIMITED - 10-14 Gresham Street, Belfast, BT1 1JN, Northern Ireland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI608460
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 10-14 Gresham Street
- Belfast
- BT1 1JN
- Northern Ireland 10-14 Gresham Street, Belfast, BT1 1JN, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- IRWIN, Richard Stephen
- Prokuristen
- SYMINGTON, Stephen Brian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.08.2011
- Gelöscht am:
- 2022-04-05
- SIC/NACE
- 56302
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Eastonville Investments Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-12-22
- Letzte Einreichung: 2021-12-08
-
MMJP LIMITED Firmenbeschreibung
- MMJP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI608460. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.08.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56302" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 10-14 Gresham Street erreicht werden.
Jetzt sichern MMJP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mmjp Limited - 10-14 Gresham Street, Belfast, BT1 1JN, Northern Ireland, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MMJP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-05) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2022-01-10) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2022-01-18) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2021
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-12-08) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-12-08) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2021-12-09) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-12) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-15) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-01-15) - AP03
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-27) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-07-29) - DISS40
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-12) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-13) - AA
-
liquidation-completion-of-voluntary-arrangement-northern-ireland (2020-12-18) - 1.4(NI)
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement-northern-ireland (2019-12-27) - 1.1(NI)
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-28) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-28) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-28) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2018-04-10) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2018-07-31) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-08-04) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-27) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-22) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-19) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-notice-compulsory (2017-08-01) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-08-05) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-22) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-16) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-11) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-04) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-08-04) - NEWINC