-
NETSOLV LIMITED - 51-53 Thomas Street, Ballymena, BT43 6AZ, Northern Ireland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI607013
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 51-53 Thomas Street
- Ballymena
- BT43 6AZ
- Northern Ireland 51-53 Thomas Street, Ballymena, BT43 6AZ, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- FALLS, Gareth Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.04.2011
- Gelöscht am:
- 2023-02-21
- SIC/NACE
- 62030
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Gareth Thomas Falls
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- INGEAR 4 SCHOOL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-10-31
- Letzte Einreichung: 2021-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-08
-
NETSOLV LIMITED Firmenbeschreibung
- NETSOLV LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI607013. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 08.04.2011 registriert. NETSOLV LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen INGEAR 4 SCHOOL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62030" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.04.2012.Die Firma kann schriftlich über 51-53 Thomas Street erreicht werden.
Jetzt sichern NETSOLV LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Netsolv Limited - 51-53 Thomas Street, Ballymena, BT43 6AZ, Northern Ireland, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NETSOLV LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-compulsory (2023-02-21) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2022
-
gazette-notice-compulsory (2022-06-28) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-08-09) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-06-30) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-29) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-29) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-15) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-02-01) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-30) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2020-01-14) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-07-02) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-29) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-30) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-29) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-08-31) - DISS40
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-13) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-31) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-18) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-13) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-06) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-28) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-08-09) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-08) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2014-08-08) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-08) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-08) - AR01
-
resolution (2013-07-08) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-07-08) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-29) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-07-08) - SH08
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-05-11) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2012-04-26) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-04-26) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-04-08) - NEWINC