-
DMC FILM LIMITED - 25 Atlantic Avenue, Ballycastle, Antrim, BT54 6AL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI603721
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25 Atlantic Avenue
- Ballycastle
- Antrim
- BT54 6AL 25 Atlantic Avenue, Ballycastle, Antrim, BT54 6AL UK
Management
- Geschäftsführung
- FASSBENDER, Michael
- MCCAUGHAN, Conor Anthony
- Prokuristen
- EMMERSON, Daniel
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-07 13 Jahre
- SIC/NACE
- 59111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Conor Anthony Mccaughan
- Mr Michael Fassbender
- Mr Michael Fassbender
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MOYNE SHELF COMPANY (NO. 276) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-29
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-17
- Letzte Einreichung: 2020-10-03
-
DMC FILM LIMITED Firmenbeschreibung
- DMC FILM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI603721. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.07.2010 registriert. DMC FILM LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MOYNE SHELF COMPANY (NO. 276) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 25 Atlantic Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern DMC FILM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dmc Film Limited - 25 Atlantic Avenue, Ballycastle, Antrim, BT54 6AL, Grossbritannien
- 2010-07-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DMC FILM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-09-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-23) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-23) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-16) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-16) - PSC04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-28) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-04-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-26) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-15) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-20) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-03-09) - AP03
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-02-04) - CH03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-03-09) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-06) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-03) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-of-name-notice (2010-10-08) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2010-10-08) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-14) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-10-14) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-10-14) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-10-14) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-14) - AD01
-
incorporation-company (2010-07-07) - NEWINC