-
DAVID JAMESON PROPERTIES LIMITED - Roundstone House, 9 Chasewood Gardens, Long Lane, Portadown, Co Armagh, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI062362
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Roundstone House
- 9 Chasewood Gardens
- Long Lane
- Portadown, Co Armagh
- BT63 5TZ Roundstone House, 9 Chasewood Gardens, Long Lane, Portadown, Co Armagh, BT63 5TZ UK
Management
- Geschäftsführung
- JAMESON, David John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.12.2006
- Alter der Firma 2006-12-18 17 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr David James Jameson
- Mrs Helen Elizabeth Jameson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-01
- Letzte Einreichung: 2020-12-18
-
DAVID JAMESON PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- DAVID JAMESON PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI062362. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.12.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Roundstone House erreicht werden.
Jetzt sichern DAVID JAMESON PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: David Jameson Properties Limited - Roundstone House, 9 Chasewood Gardens, Long Lane, Portadown, Co Armagh, Grossbritannien
- 2006-12-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DAVID JAMESON PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-06-04) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-04-06) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-20) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-18) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-18) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-26) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-20) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-26) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-12-20) - TM02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-20) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-19) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-01-19) - CH03
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-21) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-05-12) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-07) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-02-07) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2014-02-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-02-07) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-14) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-secretary-company-with-name (2010-02-08) - TM02
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-03-15) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-23) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-18) - 371S(NI)
-
legacy (2008-10-08) - AC(NI)
-
legacy (2008-02-27) - 371SR(NI)
keyboard_arrow_right 2007
-
particulars-of-a-mortgage-charge (2007-06-15) - 402(NI)
-
legacy (2007-01-08) - 296(NI)
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-12-18) - NEWINC