-
CROMWELL COURT LIMITED - Suite 2b Cadogan House, 322 Lisburn Road, Belfast, Co. Antrim, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI040514
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 2b Cadogan House
- 322 Lisburn Road
- Belfast
- Co. Antrim
- BT9 6GH
- Northern Ireland Suite 2b Cadogan House, 322 Lisburn Road, Belfast, Co. Antrim, BT9 6GH, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- MCFARLAND, Darin
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.03.2001
- Alter der Firma 2001-03-30 23 Jahre
- SIC/NACE
- 98000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alex Fleck
- -
- Mr Darin Mcfarland
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-28
- Letzte Einreichung: 2021-06-14
-
CROMWELL COURT LIMITED Firmenbeschreibung
- CROMWELL COURT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI040514. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.03.2001 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "98000" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Suite 2B Cadogan House erreicht werden.
Jetzt sichern CROMWELL COURT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cromwell Court Limited - Suite 2b Cadogan House, 322 Lisburn Road, Belfast, Co. Antrim, Grossbritannien
- 2001-03-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CROMWELL COURT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-22) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-10-23) - DISS40
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-10-19) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-30) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2021-09-07) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-11-17) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-16) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-11-16) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-31) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2020-10-20) - GAZ1
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-16) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-04) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-08-20) - GAZ1
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-01) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-01) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-01) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-01) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-09-07) - DISS40
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-07) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-02-25) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-19) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-08) - TM01
-
resolution (2015-04-13) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-13) - CH01
-
resolution (2015-04-21) - RESOLUTIONS
-
resolution (2015-05-07) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-03-31) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-22) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-19) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-19) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-19) - TM01
-
administrative-restoration-company (2015-03-13) - RT01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-03-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
gazette-dissolved-compulsory (2010-10-01) - GAZ2
-
gazette-notice-compulsory (2010-06-11) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-12-13) - AC(NI)
-
legacy (2007-01-25) - 295(NI)
-
legacy (2007-01-25) - 296(NI)
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-05-02) - 296(NI)
-
legacy (2006-05-23) - AC(NI)
-
legacy (2006-07-21) - 295(NI)
-
legacy (2006-08-15) - 371S(NI)
-
legacy (2006-06-25) - 296(NI)
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-05-24) - 371S(NI)
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-10-29) - AC(NI)
-
legacy (2003-06-11) - 371S(NI)
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-04-29) - 371S(NI)
keyboard_arrow_right 2001
-
legacy (2001-03-30) - MEM(NI)
-
legacy (2001-03-30) - ARTS(NI)
-
legacy (2001-03-30) - G23(NI)
-
legacy (2001-03-30) - G21(NI)
-
miscellaneous (2001-03-30) - MISC