-
FISHAWACK HEALTH MIDCO 2 LIMITED - 3 Booths Park, Booths Hall, Knutsford, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 12357948
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 Booths Park
- Booths Hall
- Knutsford
- Cheshire
- WA16 8GS
- England 3 Booths Park, Booths Hall, Knutsford, Cheshire, WA16 8GS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FLOCKHART, Gail Louise
- KOCH, Jonathan
- Prokuristen
- VERNON, Amanda Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.12.2019
- Alter der Firma 2019-12-10 4 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Fishawack Health Midco 1 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- COMMERCIAL SERVICES MIDCO 2 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-23
- Letzte Einreichung: 2022-12-09
-
FISHAWACK HEALTH MIDCO 2 LIMITED Firmenbeschreibung
- FISHAWACK HEALTH MIDCO 2 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 12357948. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.12.2019 registriert. FISHAWACK HEALTH MIDCO 2 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen COMMERCIAL SERVICES MIDCO 2 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3 Booths Park erreicht werden.
Jetzt sichern FISHAWACK HEALTH MIDCO 2 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fishawack Health Midco 2 Limited - 3 Booths Park, Booths Hall, Knutsford, Cheshire, Grossbritannien
- 2019-12-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FISHAWACK HEALTH MIDCO 2 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
legacy (2023-03-28) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-03-28) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-05-04) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-05-17) - AA
-
capital-allotment-shares (2023-06-12) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-10-14) - TM01
-
legacy (2023-11-11) - GUARANTEE2
-
auditors-resignation-company (2023-03-16) - AUD
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-12-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-06-27) - AP01
-
capital-allotment-shares (2022-02-11) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-20) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-04-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-20) - CS01
-
change-account-reference-date-company (2021-01-26) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-11-09) - AA
-
capital-allotment-shares (2021-06-02) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-09-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-statement-directors-reduction-of-capital-following-redomination (2020-04-27) - SH18
-
capital-reduction-of-capital-redomination (2020-04-27) - SH15
-
capital-redomination-of-shares (2020-04-27) - SH14
-
resolution (2020-04-27) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-03) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-01) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-04-01) - MR01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-02) - PSC05
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-08-30) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-08-30) - AA01
-
capital-allotment-shares (2020-04-27) - SH01
-
resolution (2020-05-01) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-12-10) - AA01
-
incorporation-company (2019-12-10) - NEWINC