-
OXYGEN TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED - 10 Horsted Square, Bellbrook Business Park, Uckfield, TN22 1QG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 11801574
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 10 Horsted Square
- Bellbrook Business Park
- Uckfield
- TN22 1QG
- United Kingdom 10 Horsted Square, Bellbrook Business Park, Uckfield, TN22 1QG, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BAILEY, Oliver Roy
- EASTER, Rafe Alexander
- HEARN, Matthew Leslie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.02.2019
- Alter der Firma 2019-02-01 5 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Rafe Alexander Easter
- Mr Oliver Roy Bailey
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-27
- Letzte Einreichung: 2022-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-15
- Letzte Einreichung: 2023-06-01
-
OXYGEN TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- OXYGEN TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 11801574. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.02.2019 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 10 Horsted Square erreicht werden.
Jetzt sichern OXYGEN TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Oxygen Technical Solutions Limited - 10 Horsted Square, Bellbrook Business Park, Uckfield, TN22 1QG, Grossbritannien
- 2019-02-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OXYGEN TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2024-03-16) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2024-01-30) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-03-15) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2024-03-12) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2023
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-08-25) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-07) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-05-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2022-08-30) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-05-10) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-02-24) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-03-11) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-12-22) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-09) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-08-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-17) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-05-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-11-26) - MR04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-08-13) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-01) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-08) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-06) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-23) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-19) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-19) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-21) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-21) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-24) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-09-12) - MR01
-
capital-allotment-shares (2019-10-22) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2019-11-04) - SH02
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-11-04) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-11-04) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-08-29) - MR01
-
incorporation-company (2019-02-01) - NEWINC