-
NG LOGISTICS HOLDINGS LIMITED - Recovery House Hainault Business Park, 15-17 Roebuck Road, Ilford, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 11293565
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Recovery House Hainault Business Park
- 15-17 Roebuck Road
- Ilford
- Essex
- IG6 3TU Recovery House Hainault Business Park, 15-17 Roebuck Road, Ilford, Essex, IG6 3TU UK
Management
- Geschäftsführung
- JOHAL, Navinder Singh
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.04.2018
- Alter der Firma 2018-04-05 6 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Navinder Singh Johal
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-11
- Letzte Einreichung: 2020-03-30
-
NG LOGISTICS HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- NG LOGISTICS HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 11293565. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.04.2018 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.07.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Recovery House Hainault Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern NG LOGISTICS HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ng Logistics Holdings Limited - Recovery House Hainault Business Park, 15-17 Roebuck Road, Ilford, Essex, Grossbritannien
- 2018-04-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NG LOGISTICS HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-10) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-06) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-06) - GAZ1
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-02-18) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-18) - TM01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-08-10) - LIQ02
-
resolution (2021-08-10) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-08-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-30) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-02-12) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-30) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-13) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-05) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-30) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-29) - AP01
-
legacy (2019-09-10) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-09-10) - SH19
-
legacy (2019-09-10) - CAP-SS
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-08-12) - AA01
-
resolution (2019-07-31) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-07-25) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-23) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-15) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-15) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
incorporation-company (2018-04-05) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-05) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-04-05) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-10) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-04) - AD01
-
capital-allotment-shares (2018-05-24) - SH01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-04-30) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-04-30) - SH08
-
resolution (2018-04-26) - RESOLUTIONS