-
MINERVA PARENT LIMITED - Abel Smith House, Gunnels Wood Road, Stevenage, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 11279426
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Abel Smith House
- Gunnels Wood Road
- Stevenage
- Hertfordshire
- SG1 2ST
- England Abel Smith House, Gunnels Wood Road, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2ST, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FINDLAY, Andrew Robert
- KEEN, Christian
- BADEL, Alexandra Nelia
- Prokuristen
- BADEL, Alexandra Nelia
- MORRILL, Ben Nicholas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.03.2018
- Alter der Firma 2018-03-27 6 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Minerva Debtco Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- DMWSL 879 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-29
- Letzte Einreichung: 2023-03-15
-
MINERVA PARENT LIMITED Firmenbeschreibung
- MINERVA PARENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 11279426. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.03.2018 registriert. MINERVA PARENT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DMWSL 879 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 2 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Abel Smith House erreicht werden.
Jetzt sichern MINERVA PARENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Minerva Parent Limited - Abel Smith House, Gunnels Wood Road, Stevenage, Hertfordshire, Grossbritannien
- 2018-03-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MINERVA PARENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-01-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-01-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2023
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-11-20) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-11-20) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-11-22) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-08-14) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-11-16) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-03) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-09-22) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2022-09-22) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-28) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-09-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-08-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-09-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-08-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-10-22) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-12-16) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-25) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-12-24) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-12-23) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-03) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-10-02) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-02) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2018-04-04) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-17) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-16) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-07-27) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-13) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-08) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-06-08) - PSC09
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-16) - AP01
-
incorporation-company (2018-03-27) - NEWINC
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-12) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-12) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-04-12) - TM02
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-04-12) - PSC08