-
PROJECT GEORGIA TOPCO LIMITED - React House Spedding Road, Fenton Industrial Estate, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 11204248
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- React House Spedding Road
- Fenton Industrial Estate
- Stoke On Trent
- Staffordshire
- ST4 2ST
- United Kingdom React House Spedding Road, Fenton Industrial Estate, Stoke On Trent, Staffordshire, ST4 2ST, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- EDWARDS, Jay Lee
- HAMMOND, John Samuel
- METCALFE, Richard
- MORLEY, Andrew Patrick
- SKELLY, Jarlath Partrick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.02.2018
- Alter der Firma 2018-02-13 6 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Barlow
- Northedge Capital Nominee Limited, As Nominee For Northedge Capital Fund Ii Lp And Northedge Capital Co-Investment Ii Lp
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-26
- Letzte Einreichung: 2021-02-12
-
PROJECT GEORGIA TOPCO LIMITED Firmenbeschreibung
- PROJECT GEORGIA TOPCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 11204248. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.02.2018 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über React House Spedding Road erreicht werden.
Jetzt sichern PROJECT GEORGIA TOPCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Project Georgia Topco Limited - React House Spedding Road, Fenton Industrial Estate, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
- 2018-02-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROJECT GEORGIA TOPCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-05) - TM01
-
memorandum-articles (2021-05-25) - MA
-
resolution (2021-05-25) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-28) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-07-21) - SH01
-
resolution (2021-08-02) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-10-16) - AA
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-04-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-26) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-18) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-01-14) - SH03
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2020-01-07) - SH10
-
resolution (2020-01-07) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2020-01-03) - SH06
-
capital-allotment-shares (2020-01-03) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-20) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-21) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-21) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
incorporation-company (2018-02-13) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-26) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-27) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-04) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-05-11) - AA01
-
capital-allotment-shares (2018-05-11) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-05-08) - SH01
-
resolution (2018-05-16) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-05-17) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-06-07) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-06-08) - SH10
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-09-14) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-14) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-05) - AP01
-
capital-allotment-shares (2018-05-09) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-05-16) - SH01