-
SHL DEBTCO LIMITED - The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, KT7 0NE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 11175000
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Pavilion
- 1 Atwell Place
- Thames Ditton
- KT7 0NE
- England The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, KT7 0NE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BRADSHAW, Andrew James
- EDMONDSON, Michael
- MOODY, James John
- JENKINS, Kerry
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.01.2018
- Alter der Firma 2018-01-29 6 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Shl Global Holdings 2 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- ACULEUS DEBTCO LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800ZKOZPMQ8TQ5C63
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-25
- Letzte Einreichung: 2024-01-11
-
SHL DEBTCO LIMITED Firmenbeschreibung
- SHL DEBTCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 11175000. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.01.2018 registriert. SHL DEBTCO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ACULEUS DEBTCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Pavilion erreicht werden.
Jetzt sichern SHL DEBTCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Shl Debtco Limited - The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, KT7 0NE, Grossbritannien
- 2018-01-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SHL DEBTCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2024-05-14) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-01-11) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-05-16) - MR04
keyboard_arrow_right 2023
-
legacy (2023-10-20) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-10-20) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-11-08) - GUARANTEE2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-11-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-24) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-01-31) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-02-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-31) - TM01
-
legacy (2022-10-10) - PARENT_ACC
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-11) - CS01
-
legacy (2022-10-10) - GUARANTEE2
-
legacy (2022-10-10) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2022-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-08-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-26) - CS01
-
legacy (2021-05-28) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-05-27) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-05-29) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-10) - TM01
-
legacy (2020-08-03) - PARENT_ACC
-
legacy (2020-08-03) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-08-03) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-27) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-01-27) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-10-05) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-09) - AA
-
legacy (2019-10-23) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-04-11) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-20) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-10) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-29) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-01-29) - AA01
-
incorporation-company (2018-01-29) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2018-05-01) - SH01