-
NAMENE SERVICE COMPANY LIMITED - 51 Holland Street, London, W8 7JB, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10945475
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 51 Holland Street
- London
- W8 7JB
- England 51 Holland Street, London, W8 7JB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LAGRANGE, Patrick Joel Xavier
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.09.2017
- Alter der Firma 2017-09-04 6 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- YINGLI NAMENE SERVICE COMPANY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-17
- Letzte Einreichung: 2023-09-03
-
NAMENE SERVICE COMPANY LIMITED Firmenbeschreibung
- NAMENE SERVICE COMPANY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10945475. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.09.2017 registriert. NAMENE SERVICE COMPANY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen YINGLI NAMENE SERVICE COMPANY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 51 Holland Street erreicht werden.
Jetzt sichern NAMENE SERVICE COMPANY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Namene Service Company Limited - 51 Holland Street, London, W8 7JB, England, Grossbritannien
- 2017-09-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NAMENE SERVICE COMPANY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-07) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-03-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-05) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-02-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-10-13) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-06-27) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-06-09) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-01-03) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-01-03) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-01-03) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-20) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-08-04) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-01) - MR01
-
resolution (2020-07-01) - RESOLUTIONS
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2020-12-28) - CH03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-12-23) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-01) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-12-28) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-10) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-31) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-05-07) - PSC08
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-10) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-09-10) - TM02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-05) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-15) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-11-09) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-15) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-09-15) - AP03
-
incorporation-company (2017-09-04) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-09) - AD01